L'INSTITUT DE DÉVELOPPEMENT URBAIN DU QUÉBEC - MONTRéAL QC CANADA


Company Information

L'INSTITUT DE DÉVELOPPEMENT URBAIN DU QUÉBEC is a company from Montréal QC Canada. The company has corporate status: Active.

L'INSTITUT DE DÉVELOPPEMENT URBAIN DU QUÉBEC - MONTRéAL QC CANADA

811337

L'INSTITUT DE DÉVELOPPEMENT URBAIN DU QUÉBEC is governed under the Canada Not-for-profit Corporations Act - 2014-09-24. It a company of type: Non-Soliciting.
The date of the company's last Annual Meeting is 2023-06-06.
The status of its annual filings are: 2024 - Not due, 2023 -Filed, 2022 -Filed.
This company has had the following names:
  • L'INSTITUT DE DÉVELOPPEMENT URBAIN DU QUÉBEC - 2014-09-24 to Present
  • L'INSTITUT DE DEVELOPPEMENT URBAIN DU QUEBEC - 1987-08-25to 2014-09-24
L'INSTITUT DE DÉVELOPPEMENT URBAIN DU QUÉBEC has between 10 and 25 directors.

Address & Map

2115-1010 rue de la Gauchetière Ouest Montréal QC H3B 2N2, Canada

Company Officers

Name Address Town Country
Roger Plamondon 500-16766 RTE Trans-Canadienne Kirkland QC H9H 4M7 Canada
Yves Godin 1600-1100 boul. René-Lévesque O. Montréal QC H3B 4N4 Canada
Martin Raymond 1800 Avenue McGill College, Bureau 1900 Montréal QC H3A 3J6 Canada
Mathieu Jobin 3400 rue de l'Éclipse Brossard QC J4Z 0P3 Canada
Jean-Marc Fournier 1010 rue de la Gauchetière Ouest Montréal QC H3B 2N2 Canada
Laurence Vincent 1020 Rue William Montréal QC H3C 1P6 Canada
Emeka Mayes 1800 Avenue McGill College, bureau 400 Montréal QC H3A 3J6 Canada
Stéphane Coté 810-407 Rue McGill Montréal QC H2Y 2G3 Canada
Brett Miller 900-2000 rue Peel Montréal QC H3A 2W5 Canada
Nathalie Rousseau 1001 Rue du Square-Victoria Montréal QC H2Z 0A4 Canada
Claude Sirois 2000 Av. McGill College Montréal QC H3A 3J1 Canada
James Papadimitriou 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2500 Montréal QC H3B 0A2 Canada
Pierre-Jacques Lefaivre 630 rue St-Paul Montréal QC H3C 1L9 Canada
Louise N Pelletier 8500 Bd Décarie 8e étage Mont-Royal QC H4P 2N2 Canada
Steven Bouffard 2820 boul Laurier Québec QC G1V 0C1 Canada
Brian Salpeter 1100 Avenue des Canadiens-de-Montréal, Bureau 400 Montréal QC H3B 2S2 Canada
ANTHONY ARQUIN 1501, avenue McGill College, 26e étage Montréal QC H3A 3N9 Canada
David Grenier 75 rue rené-lévesque Montréal QC H2Z 1A4 Canada
Seneva Snyder-Caron 16700 autoroute Félix Leclerc Kirkland QC H9H 4M7 Canada
Irene Peng 503-1425 Rene-Levesque Ouest Montréal QC H3G 1T7 Canada

Related Companies

Name Address Town Country Status
Défi Canderel 900-2000 Peel Street Montreal QC, H3A 2W5 Canada Active
LES IMMEUBLES CARREFOUR CLAUDE-ROBUTEL INC. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2500 Montréal QC, H3B 0A2 Canada Inactive - Discontinuedon 2014-12-23
Wilkar Property Management Inc. 4200 Sherbrooke O. #6 Westmount QC, H3Z 1C4 Canada Active
LES IMMEUBLES CARREFOUR ALEXANDER GRAHAM BELL INC. 1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2500 Montréal QC, H3B 0A2 Canada Inactive - Discontinuedon 2014-12-23

Nearby Businesses

Name Address Town Country Status
PGM Global Inc. 1010 Rue De la Gauchetière Ouest, Suite 2010 Montréal QC, H3B 2N2 Canada Active
TIMMINS & ASSOCIATES LIMITED 2050 PLACE DU CANADA MONTREAL QC, H3B 2N2 Canada Inactive - Amalgamated intoT.A.L. INVESTMENT COUNSEL LTD. - / LES PLACEMENTS T.A.L. LTÉEon 1987-06-18
U.F. FINANCIAL SERVICES INC. PLACE DU CANADA, SUITE 1020 MONTREAL QC, H3B 2N2 Canada Inactive - Amalgamated intoACCORD BUSINESS CREDIT INC. / LES SERVICES DE CREDIT ACCORD INC.on 1992-04-21
PLACEMENTS Y. AMIOUNY INC. 1010 DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1315 MONTREAL QC, H3B 2N2 Canada Inactive - Amalgamated intoIMMOBILIER AMIOUNY INC. / AMIOUNY REAL ESTATE INC.on 2011-01-01
T.A.L. INVESTMENT COUNSEL LTD. - 1900 PLACE DU CANADA MONTREAL QC, H3B 2N2 Canada Inactive - Amalgamated intoT.A.L. INVESTMENT COUNSEL LTD. / LES PLACEMENTS T.A.L. LTÉEon 1989-12-30
MONDIAL HOSPITAL MATERIAL M.H.M. INC. PLACE DU CANADA, SUITE 1020 MONTREAL QC, H3B 2N2 Canada Dissolved for non-compliance (s. 212)on 1995-11-08
PARTS ON THE GO INC. 1010 DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1020 MONTRÉAL QC, H3B 2N2 Canada Dissolved by the corporation (s. 210)on 2003-11-27
MAS KADIMA SALES INC. 1010 DE LA GAUCHETIERE WEST, SUITE 1020 MONTREAL QC, H3B 2N2 Canada Dissolved by the corporation (s. 210)on 2006-10-16
Association des Jeux des Maîtres d'Hiver et d'Été CA 1010 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 1400 MONTREAL QC, H3B 2N2 Canada Dissolved - Part II of CCAon 2006-04-03
MAS MACHINING & FABRICATION GROUP INC. 1010 DE LA GAUCHETIERE STREET W., SUITE 1020 MONTREAL QC, H3B 2N2 Canada Dissolved for non-compliance (s. 212)on 2019-01-14